Esta sección contiene solo alertas del estado de NY. Para ver las alertas nacionales, visite http://www.vuwriter.com/
Fecha de publicación
Número de alerta
Sujeto
12/12/2008
250 Chestnut Drive, Roslyn, NY
25/11/2008
Jerry Kuhr y/o Amanda Kuhr
20/11/2008
15 Gunther Place, Brooklyn, NY
17/11/2008
384 Vanderbilt Avenue, Brooklyn, NY
13/11/2008
630 Central Avenue también conocida como 150 Scaetter Street, Brooklyn, NY
3/10/2008
47 Meade Court, Babylon, NY
24/9/2008
36 Gladys Drive, Unidad 26-6, Spring Valley
23/9/2008
Varios nombres y direcciones
10/9/2008
Woodside Group LLC. Haga clic aquí para ver el orden del Capítulo 11.
27/8/2008
Varios nombres y direcciones
18/8/2008
10 Stryker Street y 1976 East 23rd Street, Brooklyn, NY
14/8/2008
378 Amboy Street, Brooklyn, NY
12/8/2008
227 Tremont Road, Lindenhurst, NY
31/7/2008
548 17th Street, Brooklyn
29/7/2008
4618 Snyder Avenue, Brooklyn
16/7/2008
126 Fort Hill Road, Scarsdale
26/6/2008
1727 East 93rd Street, Brooklyn
18/6/2008
Adesh Harrycharan
13/6/2008
22 St. Andrews Place
12/6/2008
198 Cedar Lane Road
3/6/2008
Thomas Howard y/o servicios de título
21/5/2008
Quiebra de Kimball Hill
\
(Kimball Hill, Inc., et al.)
16/5/2008
Kensington Realty Deveopment LLC
24/4/2008
Kimball Hill Inc, o cualquiera de sus filiales
21/4/2008
330 East 33rd Street, Unit 11E, Nueva York NY
16/4/2008
176-29 137th Avenue, jardines Springfield
28/3/2008
Direcciones, entidades y personas diversas
24/3/2008
Dwayne Alexis Samuels
7/3/2008
Entidades de Altieri